Identity area
Reference code
Title
Date(s)
- 1919; 1922 (Creation)
Level of description
Extent and medium
Textuais. 1v. 317f.
Context area
Name of creator
Biographical history
Name of creator
Biographical history
Name of creator
Biographical history
Name of creator
Biographical history
Name of creator
Biographical history
Name of creator
Biographical history
Name of creator
Biographical history
Name of creator
Biographical history
Name of creator
Biographical history
Name of creator
Biographical history
Name of creator
Biographical history
Name of creator
Biographical history
Name of creator
Biographical history
Name of creator
Biographical history
Name of creator
Biographical history
Archival history
Immediate source of acquisition or transfer
Content and structure area
Scope and content
O autor, estado civil casado, residente na Rua Cosme Velho 139, alegou que havia sido contratado pela ré como comandante do vapor Ubatuba para seguir viagem para o porto de Gênova, mediante uma soldada no valor de 800$000 réis mensais mais 30 por cento por navegação em zona de guerra. O suplicante requereu, conforme o Regulamento 737 de 1850 artigos 292 e 293, o pagamento de suas soldadas vencidas no valor total de 8:105$898 réis. O juiz deferiu o requerido inical, decisão esta que foi contestada pela ré e o juiz ratificou sua decisão. A ré apelou da decisão para o Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo. A ré entrou com pedido de embargo de nulidade do acordão e o Supremo rejeitou. Procuração, Tabelião Belisário Fernandes da Silva Távora, Rua Buenos Aires, 46 - RJ, 1916, Tabelião Eduardo Carneiro de Mendonça, Rua do Rosário, 116 - RJ, 1917, 1920, Tabelião Pedro Evangelista de Castro, Rua do Rosário, 57 - RJ, 1921; Taxa Judiciária, 1919; Termo de Apelação, 1919; Termo de Agravo, 1920; Jornal Diário Oficial, 15/11/1918; Recibo, Recebedoria do Distrito Federal, 1919; Conta Corrente do autor com a Lloyd Nacional, 1919, 1918; Recibo, 1918; Lista de pagamento dos tripulantes do vapor Ubatuba, 1919; Ordem de Pagamento, Lloyd Nacional, 1918; Planilha Orçamentária, Lloyd Nacional, 1919; Tradução de nota fiscal do inglês para o português por James Molimay do vapor Ubatuba, 1919; Taxa Judiciária, 1919; Custas Processuais, 1920, 1923; Termo de Agravo, 1920; Recorte de Jornal Diário Oficial, 13/11/1918; Regulamento nº 737 de 1850, artigos 292, 293, 297 e 294; Código Comercial, artigos 535 e 131; Decreto nº 3084 de 1898, artigo 501; Constituição Federal, artigo 72; Decreto nº 848 de 1890, artigos 351, 252 e 90; Lei nº 221 de 20/11/1894, artigo 54.
Appraisal, destruction and scheduling
Accruals
System of arrangement
Conditions of access and use area
Conditions governing access
Ver art. 3º ao art. 12 da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00014, de 28/03/2019 (Disponível em https://www10.trf2.jus.br/memoria/wp-content/uploads/sites/48/2019/04/rsp14.pdf ).
Conditions governing reproduction
Ver art. 13 ao art. 17 da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00014, de 28/03/2019 (Disponível em https://www10.trf2.jus.br/memoria/wp-content/uploads/sites/48/2019/04/rsp14.pdf ).
Language of material
- Brazilian Portuguese
- Italian
- English
- French
Script of material
Language and script notes
Physical characteristics and technical requirements
Formulário impresso preenchido e documento manuscrito em bom estado de conservação.
Finding aids
Allied materials area
Existence and location of originals
Existence and location of copies
Related units of description
Notes area
Note
Pasta 02
Alternative identifier(s)
Autor
Réu
Ministro do STF
Escrivão
Access points
Subject access points
Place access points
Name access points
- Compania Comercialle Martinelli (Subject)
- Mercearia Saraiva (Subject)
- Bought of James Molinary (Subject)
- Fillipo Cambinio (Subject)
- J. S. Wood & Company (Subject)
Genre access points
Description control area
Description identifier
Institution identifier
Rules and/or conventions used
Status
Level of detail
Dates of creation revision deletion
8/7/2007
Language(s)
Script(s)
Sources
Archivist's note
Stefan